-
INNO FRICTION GmbH - Industriestraße 7, 57577 Hamm/Sieg, Germany
Company Information
- Company registration number
- HRB13478 MONTABAUR
- Company Status
- LIVE
- Country
- Germany
- Registered Address
- Industriestraße 7
- 57577 Hamm/Sieg Industriestraße 7, 57577 Hamm/Sieg DE
Management
- Managing Directors
- Stefan Löhr (Geschaeftsfuehrer)
- Vera Rührup (Geschaeftsfuehrer)
- Christian Spandern (Geschaeftsfuehrer)
- Frank Steinhauer (Geschaeftsfuehrer)
- Company secretaries
- Martin Meier (Prokura)
Company Details
- Type of Business
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Incorporated
- 1997-06-25
- Dissolved on
- -
- Age Of Company 1997-06-25 26 years
Ownership
- Share Capital
- 550.000,00 EUR
Jurisdiction Particularities
- Additional Status Details
- aktuell
- Court
- DE/Montabaur
- Previous Names
- LuK Friction GmbH
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 529900SB8RITN5H0QP44
- VAT Number
- DE134167210
- Website
- www.aptec.de
- email address
- info@innofriction.com
- Phone
- +49 26827080
- Fax
- +49 2682708150
-
INNO FRICTION GmbH Company Description
- INNO FRICTION GmbH is a Gesellschaft mit beschränkter Haftung registered in Germany with the Company reg no HRB13478 MONTABAUR. Its current trading status is "live". It was registered 1997-06-25. It was previously called LuK Friction GmbH. and 1 secretary. The managing director is Stefan Löhr,Vera Rührup,Christian Spandern,Frank Steinhauer.It can be contacted at Industriestraße 7 by phone on +49 26827080 by email at info@innofriction.com by fax on +49 2682708150 on the web at www.aptec.de.
Get INNO FRICTION GmbH Register ReportShareholder ListArticles of AssociationAnnual AccountChronological Extract
You are here: Inno Friction Gmbh - Industriestraße 7, 57577 Hamm/Sieg, Germany
- 1997-06-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- years
-
Announcements from the Handelsregister
- 2020-05-28 Modification
- HRB *: INNO FRICTION GmbH, Hamm/Sieg, Industriestr. *, D-* Hamm (Sieg) Die Gesellschafterversammlung vom *.*.* hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Geändert, nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Nach Änderung der Vertretungsmacht, nun: Geschäftsführer: Löhr, Stefan, Mudenbach, **.*.*; Dr. Rührup, Vera, Morsbach-Ellingen, **. *.*; Dr. Spandern, Christian, Elkenroth, **.*.*; Steinhauer, Frank, Forst, **.*.*, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
-
INNO FRICTION GmbH
Did you know? kompany provides original and official company documents for INNO FRICTION GmbH as filed with the government register. Guaranteed.
Register Report
Official proof of the company existence
Shareholder List
Details on the shareholders
Articles of Association
Founding documents
Annual Account
Financial data for the last reported full year
Chronological Extract
Full record of registrable changes
Official Filings
Company filings direct from the official registry.
keyboard_arrow_down 2020
-
2020-05-11 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 11.05.2020
-
2020-05-11 - Anmeldung vom 11.05.2020
-
2020-05-25 - Anmeldung vom 25.05.2020
-
2020-05-14 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 14.05.2020
keyboard_arrow_right 2019
-
2019-06-26 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 26.06.2019
-
2019-07-09 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 09.07.2019
-
2019-06-27 - Anmeldung vom 27.06.2019
-
2019-07-01 - Anmeldung vom 01.07.2019
-
2019-07-10 - Anmeldung vom 10.07.2019
-
2019-07-12 - Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 12.07.2019
-
2019-06-26 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 26.06.2019
keyboard_arrow_right 2018
-
2018-02-20 - Anmeldung vom 20.02.2018
-
2018-03-01 - Amtsniederlegung vom 01.03.2018
-
2018-04-16 - Anmeldung vom 16.04.2018
-
2018-03-02 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 02.03.2018
-
2018-12-17 - Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 17.12.2018
keyboard_arrow_right 2017
-
2017-12-20 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 20.12.2017
-
2017-07-19 - Anmeldung vom 19.07.2017
-
2017-02-07 - Anmeldung vom 07.02.2017
-
2017-01-16 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 16.01.2017
keyboard_arrow_right 2012
-
2012-09-17 - Anmeldung vom 17.09.2012
-
2012-05-16 - Anmeldung vom 16.05.2012
-
2012-03-05 - Anmeldung vom 05.03.2012
-
2012-04-10 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 10.04.2012
keyboard_arrow_right 2010
-
2010-05-17 - Anmeldung vom 17.05.2010
-
2010-04-16 - Anmeldung vom 16.04.2010
-
2010-03-16 - Anmeldung vom 16.03.2010
-
2010-04-16 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 16.04.2010
-
2010-04-19 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 19.04.2010
-
2010-04-16 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 16.04.2010
-
2010-03-16 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 16.03.2010
-
2010-04-om 19 - => Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 19.04.2010
keyboard_arrow_right 2007
-
2007-03-07 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 07.03.2007
-
2007-03-22 - Sonstige Urkunde - Unterlage vom 22.03.2007
keyboard_arrow_right 2010
-
2010-04-ed 19 - => Report - decision - record dated 19-04-2010
keyboard_arrow_right 2007
-
2007-03-07 - Anmeldung vom 07.03.2007
keyboard_arrow_right 2006
-
2006-12-30 - Sonstige Urkunde - Unterlage vom 30.12.2006